TRIFON ALQUILERES SL
Dirección social Calle Marques de Berlanga, 50
Código Postal 09006
Municipio Burgos
Provincia Burgos
Mapa Ver Mapa
Razón Social TRIFON ALQUILERES SL
CIF B09436957
Capital Social 7460140.88 Euros
Fecha de Constitución 17/12/2004
Teléfono 94 722 21 33
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Gonzalez Ortega Maria Belen
ORGANIGRAMA DE TRIFON ALQUILERES SL
VINCULACIONES DE TRIFON ALQUILERES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRIFON ALQUILERES SL
| Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Gonzalez Ortega Felix Carmelo | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/01/2026 | |
| Gonzalez Ortega Jesus Cruz | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/01/2026 | |
| Gonzalez Ortega Sinaita Visitacion | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/01/2026 | |
| Valladolid Olmo Monica | Apoderado Solidario | 30/01/2026 | |
| Yañez Blanco Carlos | Apoderado Solidario | 30/01/2026 | |
| Gonzalez Rodriguez Beltran | Apoderado | 23/12/2022 | |
| Gonzalez Ortega Felix Carmelo | Apoderado Solidario | 04/01/2018 | |
| Gonzalez Ortega Jesus Cruz | Apoderado Solidario | 04/01/2018 | |
| Gonzalez Ortega Jesus Cruz | Secretario | 24/05/2012 | |
| Gonzalez Ortega Maria Belen | Presidente | 24/05/2012 |
ACTOS BORME DE TRIFON ALQUILERES SL
- Sociedades absorbidas: Sociedad Constructora Promotora J Gonzalez Alonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BU 10301, I/A 17 (30/01/2026)
CVE: BORME-A-2026-26-09
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BU 10301, I/A 16 (30/01/2026)
CVE: BORME-A-2026-26-09
| Capital Anterior: | 9.325.170,09 | Euros |
| Disminución de capital | 1.865.029,21 | Euros |
| Capital Actual: | 7.460.140,88 | Euros |
| Porcentaje: | 20,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 803, L 594, F 96, S 8, H BU 10301, I/A 14 (26/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-102-09
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 803, L 594, F 96, S 8, H BU 10301, I/A 14 (26/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-102-09
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 535, L 326, F 224, S 8, H BU 10301, I/A 13 (23/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-247-09
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 535, L 326, F 224, S 8, H BU 10301, I/A 12 (04/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-7-09
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo 8º. Referente a la retribución de los administradores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 535, L 326, F 224, S 8, H BU 10301, I/A 11 (20/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-247-09
- Sociedades absorbidas: APIA APARTAMENTOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 535, L 326, F 219, S 8, H BU 10301, I/A 10 (21/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-189-09
- Absorbidas: APIA APARTAMENTOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (28/06/2012)
CVE: BORME-B-2012-128-09
- C/ MARQUES DE BERLANGA 50 BAJO (BURGOS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 535, L 326, F 218, S 8, H BU 10301, I/A 9 (24/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-104-09