SERVICIOS COLECTIVOS DE LA INDUSTRIA TEXTIL SA - EXTINGUIDA
Código Postal 08201
Municipio Sabadell
Provincia Barcelona
Razón Social SERVICIOS COLECTIVOS DE LA INDUSTRIA TEXTIL SA
CIF A08776429
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE SERVICIOS COLECTIVOS DE LA INDUSTRIA TEXTIL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SERVICIOS COLECTIVOS DE LA INDUSTRIA TEXTIL SA
| Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Bombardo Navines Jose | Presidente | 30/07/2015 | 12/12/2018 |
| Bombardo Navines Jose | Consejero | 30/07/2015 | 12/12/2018 |
| Bombardo Navines Jose | Apoderado Solidario | 17/08/2015 | 12/12/2018 |
| Garcia Planas Marcet Francesc | Consejero | 30/07/2015 | 12/12/2018 |
| Garcia Planas Marcet Francesc | Apoderado Solidario | 17/08/2015 | 12/12/2018 |
| Garrell Guiu Antonio Cosme | Consejero | 30/07/2015 | 12/12/2018 |
| Garrell Guiu Antonio Cosme | Apoderado Solidario | 17/08/2015 | 12/12/2018 |
| Grau Bedos Joan Carles | Liquidador | 12/12/2018 | 12/12/2018 |
| Grau Bedos Joan Carles | Secretario | 30/07/2015 | 12/12/2018 |
| Grau Bedos Joan Carles | Consejero | 30/07/2015 | 12/12/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SERVICIOS COLECTIVOS DE LA INDUSTRIA TEXTIL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44957 , F 191, S 8, H B 118174, I/A 29 (12/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-242-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DEL ARTICULO 33 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44957 , F 191, S 8, H B 118174, I/A 29 (12/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-242-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44957 , F 191, S 8, H B 118174, I/A 29 (12/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-242-08
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44957 , F 191, S 8, H B 118174, I/A 29 (12/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-242-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27425 , F 31, S 8, H B 118174, I/A 28 (17/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DEL ARTICULO 25 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. ESTRUCTURA DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27425 , F 30, S 8, H B 118174, I/A 27 (30/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-149-08
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27425 , F 30, S 8, H B 118174, I/A 27 (30/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-149-08
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27425 , F 30, S 8, H B 118174, I/A 27 (30/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-149-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-205-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTS.13,21,25 Y 33.- CAMBIO DE REGIMEN ADMINISTRATIVO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27425 , F 29, S 8, H B 118174, I/A 26 (27/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-25-08