RUYMAR DERIVADOS DEL CAUCHO SL
Municipio Riba-roja de Túria
Provincia Valencia
Razón Social RUYMAR DERIVADOS DEL CAUCHO SL
CIF B96230610
Capital Social 72600.0 Euros
Teléfono 96 166 88 70
Página Web www.ruymar.com
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Martinez Castrense Jose Miguel
ORGANIGRAMA DE RUYMAR DERIVADOS DEL CAUCHO SL
VINCULACIONES DE RUYMAR DERIVADOS DEL CAUCHO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RUYMAR DERIVADOS DEL CAUCHO SL
| Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Albarañez Garces Francisco Javier | Consejero | 27/11/2017 | |
| Andreu Perez Maria Josefina | Secretario | 27/11/2017 | |
| Andreu Perez Maria Josefina | Consejero | 27/11/2017 | |
| Martinez Castrense Jose Miguel | Presidente | 27/11/2017 | |
| Martinez Castrense Jose Miguel | Consejero Delegado | 27/11/2017 | |
| Martinez Castrense Jose Miguel | Consejero | 27/11/2017 | |
| Albarañez Garces Francisco Javier | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/12/2014 | |
| Andreu Perez Maria Josefina | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/12/2014 | |
| Albarañez Garces Francisco Javier | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/08/2014 | |
| Andreu Perez Maria Josefina | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/08/2014 |
ACTOS BORME DE RUYMAR DERIVADOS DEL CAUCHO SL
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4730, L 2040, F 78, S 8, H V 31087, I/A 19 (27/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-230-46
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4730, L 2040, F 78, S 8, H V 31087, I/A 19 (27/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-230-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4730, L 2040, F 78, S 8, H V 31087, I/A 19 (27/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-230-46
| Capital Anterior: | 79.332,00 | Euros |
| Disminución de capital | 6.732,00 | Euros |
| Capital Actual: | 72.600,00 | Euros |
| Porcentaje: | 8,49 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4730, L 2040, F 77, S 8, H V 31087, I/A 18 (25/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-167-46
- Otras modificaciones estatutarias: Se modifica el articulo 8º estatutos en cuanto a la copropiedad, usufructo, prenda y embargo de participaciones.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4730, L 2040, F 77, S 8, H V 31087, I/A 17 (15/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-137-46
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4730, L 2040, F 76, S 8, H V 31087, I/A 16 (18/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-246-46
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4730, L 2040, F 75, S 8, H V 31087, I/A 15 (18/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-246-46
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4730, L 2040, F 75, S 8, H V 31087, I/A 14 (27/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-167-46
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4730, L 2040, F 75, S 8, H V 31087, I/A 13 (27/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-167-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4730, L 2040, F 74, S 8, H V 31087, I/A 12 (27/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-167-46