HISCOX EUROPE UNDERWRITING LIMITED - EXTINGUIDA
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social HISCOX EUROPE UNDERWRITING LIMITED
CIF W8260282B
Capital Social 0.0 Euros
Fecha de Constitución 25/03/2009
VINCULACIONES DE HISCOX EUROPE UNDERWRITING LIMITED
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HISCOX EUROPE UNDERWRITING LIMITED
| Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Bailey David | Apoderado Mancomunado | 10/07/2015 | 25/03/2019 |
| Bailey David | Apoderado | 14/04/2014 | 25/03/2019 |
| Bailey David | Apoderado | 25/07/2014 | 25/03/2019 |
| Bailey David | Apoderado | 07/10/2009 | 25/03/2019 |
| Baptista Goncalo | Apoderado | 07/10/2009 | 25/03/2019 |
| Bridges Stuart | Apoderado | 07/10/2009 | 25/03/2019 |
| Caeiro Baiao Sonia Cristina | Apoderado Solidario | 10/07/2015 | 25/03/2019 |
| Caeiro Baiao Sonia Cristina | Apoderado | 25/07/2014 | 25/03/2019 |
| Champire Anne | Apoderado Mancomunado | 10/07/2015 | 25/03/2019 |
| Champire Anne | Apoderado | 14/04/2014 | 25/03/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE HISCOX EUROPE UNDERWRITING LIMITED
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33423 , F 140, S 8, H M 479756, I/A 14 (25/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-63-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26622 , F 56, S 8, H M 479756, I/A 13 (10/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-134-28
- PASEO DE LA CASTELLANA 60, 7& PLANTA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26622 , F 56, S 8, H M 479756, I/A 12 (28/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-104-28
- CONSTANCIA DE LOS ADMINISTRADORES Y DE LA SEDE SOCIAL DE LA SOCIEDAD MATRIZ
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26622 , F 55, S 8, H M 479756, I/A 11 (27/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-103-28
Apoderado
- Bailey David
- Caeiro Baiao Sonia Cristina
- Champire Anne
- Colaco Carla
- Costa Ana
- Desaulle Pierre Olivier
- Garcia Fialho Monica Sofia
- Garcia Valverde Maria Jesus
- Gibson Scott
- Lock Rebecca
- Meca Ana
- Moreira Bras Claudia
- Morgado Elsa
- Pedro Nuno
- Pedrosa Solis Diego
- Pereira Cristina
- Rocha Vaz Baptista Patricia Alves De Jesus
- Sousa Sofia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26622 , F 54, S 8, H M 479756, I/A 10 (25/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-147-28
- SE PUBLICO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 8& EL PODER OTORGADO A BLANCA COLACO, SIENDO LO CORRECTO CARLA COLACO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26622 , F 53, S 8, H M 479756, I/A 8 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-145-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26622 , F 54, S 8, H M 479756, I/A 9 (03/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-109-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26622 , F 53, S 8, H M 479756, I/A 8 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-77-28
- C/ MARIA DE MOLINA 37-BIS 3& (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26622 , F 52, S 8, H M 479756, I/A 7 (01/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-236-28
- REVOCACION DE LOS PODERES CONFERIDOS A D. JESUS IGLESIAS MARTINEZ EN LA INSCRIPCION 1& DE CREACION DE SUCURSAL. Y SE HACE CONSTAR QUE EL SECRETARIO ACTUAL DE LA SOCIEDAD MATRIZ ESD. JOHN KEITH TAYLOR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26622 , F 52, S 8, H M 479756, I/A 7 (01/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-236-28