GRUAS Y TRANSPORTES DECA SA - EXTINGUIDA
Municipio Oroso
Provincia A Coruña
Razón Social GRUAS Y TRANSPORTES DECA SA
CIF A36633899
Capital Social 299568.0 Euros
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor PANARO AUDIT SLP
VINCULACIONES DE GRUAS Y TRANSPORTES DECA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUAS Y TRANSPORTES DECA SA
| Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Doniz Garrido David | Apoderado Mancomunado | 12/05/2021 | 04/12/2024 |
| Doniz Garrido David | Apoderado Mancomunado | 28/01/2021 | 04/12/2024 |
| Doniz Guedella Rebeca | Apoderado Mancomunado | 12/05/2021 | 04/12/2024 |
| Doniz Guedella Rebeca | Apoderado Mancomunado | 28/01/2021 | 04/12/2024 |
| Eiriz Lopez Iago | Liquidador | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| Eiriz Lopez Iago | Secr.Cons.Li | 04/12/2024 | 04/12/2024 |
| Eiriz Lopez Iago | Consejero | 12/05/2021 | 04/12/2024 |
| Eiriz Lopez Iago | Secretario | 12/05/2021 | 04/12/2024 |
| Eiriz Lopez Iago | Apoderado Mancomunado | 12/05/2021 | 04/12/2024 |
| HIDORE SL | Consejero | 30/01/2012 | 04/12/2024 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GRUAS Y TRANSPORTES DECA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H C 8793, I/A 36 (04/12/2024)
CVE: BORME-A-2024-240-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H C 8793, I/A 36 (04/12/2024)
CVE: BORME-A-2024-240-15
Pr.Cons.Liq
Secr.Cons.Li
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H C 8793, I/A 36 (04/12/2024)
CVE: BORME-A-2024-240-15
Pr.Cons.Liq
Presidente
Secr.Cons.Li
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H C 8793, I/A 36 (04/12/2024)
CVE: BORME-A-2024-240-15
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: RELATIVO AL CAPITAL SOCIAL.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2322 , F 188, S 8, H C 8793, I/A 34 (10/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-199-15
| Capital Anterior: | 306.680,00 | Euros |
| Disminución de capital | 7.112,00 | Euros |
| Capital Actual: | 299.568,00 | Euros |
| Porcentaje: | 2,32 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2322 , F 188, S 8, H C 8793, I/A 34 (10/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-199-15
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: RELATIVO AL CAPITAL SOCIAL.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2322 , F 188, S 8, H C 8793, I/A 33 (10/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-135-15
| Capital Anterior: | 360.000,00 | Euros |
| Disminución de capital | 53.320,00 | Euros |
| Capital Actual: | 306.680,00 | Euros |
| Porcentaje: | 14,81 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2322 , F 188, S 8, H C 8793, I/A 33 (10/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-135-15
- Se sustituye a Ramón Dóniz Regente como persona física representante de la Consejera y Presidenta, HIDRORE SL., por Don Pablo Carlos Provedo Dóniz.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2322 , F 188, S 8, H C 8793, I/A 32 (18/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-79-15
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2322 , F 188, S 8, H C 8793, I/A 31 (19/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-207-15